october 19 octobre

23
The Royal Gazette Fredericton New Brunswick Gazette royale Fredericton Nouveau-Brunswick Vol. 169 Wednesday, October 19, 2011 / Le mercredi 19 octobre 2011 1323 ISSN 1714-9428 Notice to Readers The Royal Gazette is officially published on-line. Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted. Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least seven working days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the Royal Gazette Coordinator at 453-8372. PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2011-290, I declare that An Act to Amend the Pension Benefits Act, Chapter 5 of the Acts of New Brunswick, 2008, comes into force October 1, 2011. This Proclamation is given under my hand and the Great Seal of the Province at Fredericton on Septem- ber 21, 2011. Marie-Claude Blais, Q.C. Graydon Nicholas Attorney General Lieutenant-Governor Proclamations Avis aux lecteurs La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis. Les documents à publier doivent parvenir à la coordon- natrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept jours ouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la Gazette royale au 453-8372. PROCLAMATION Conformément au décret en conseil 2011-290, je déclare le 1 er octobre 2011 date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension, chapitre 5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008. La présente proclamation est faite sous mon seing et sous le grand sceau de la province, à Fredericton, le 21 septembre 2011. La procureure générale, Le lieutenant-gouverneur, Marie-Claude Blais, c.r. Graydon Nicholas Proclamations

Upload: vunhan

Post on 02-Jan-2017

221 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: October 19 octobre

The RoyalGazette

FrederictonNew Brunswick

Gazetteroyale

FrederictonNouveau-Brunswick

Vol. 169 Wednesday, October 19, 2011 / Le mercredi 19 octobre 2011 1323

ISSN 1714-9428

Notice to Readers

The Royal Gazette is officially published on-line.

Except for formatting, documents are published in TheRoyal Gazette as submitted.

Material submitted for publication must be received bythe Royal Gazette Coordinator no later than noon, at leastseven working days prior to Wednesday’s publication.However, when there is a public holiday, please contactthe Royal Gazette Coordinator at 453-8372.

PROCLAMATIONPursuant to Order in Council 2011-290, I declare that An Act toAmend the Pension Benefits Act, Chapter 5 of the Acts of NewBrunswick, 2008, comes into force October 1, 2011.

This Proclamation is given undermy hand and the Great Seal of theProvince at Fredericton on Septem-ber 21, 2011.

Marie-Claude Blais, Q.C. Graydon NicholasAttorney General Lieutenant-Governor

Proclamations

Avis aux lecteurs

La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.

Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dansla Gazette royale tels que soumis.

Les documents à publier doivent parvenir à la coordon-natrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept joursouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jourférié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de laGazette royale au 453-8372.

PROCLAMATIONConformément au décret en conseil 2011-290, je déclare le1er octobre 2011 date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant laLoi sur les prestations de pension, chapitre 5 des Lois duNouveau-Brunswick de 2008.

La présente proclamation est faitesous mon seing et sous le grandsceau de la province, à Fredericton,le 21 septembre 2011.

La procureure générale, Le lieutenant-gouverneur,Marie-Claude Blais, c.r. Graydon Nicholas

Proclamations

Page 2: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1324 Gazette royale — 19 octobre 2011

The Honourable Graydon Nicholas, Lieutenant Governor ofNew Brunswick is pleased to announce, effective immediately,the appointment of Colonel P.J. (Peter) Kramers, CD, Commis-sionaires, NB & PEI Division, as Honorary Aide-de-Camp tothe Lieutenant Governor of New Brunswick.

Notices

L’honorable Graydon Nicholas, lieutenant-gouverneur duNouveau-Brunswick, est heureux d’annoncer, à compterd’aujourd’hui, la nomination de Colonel P.J. (Peter) Kramers,CD, Commissionnaires, Division du N.-B. et l’Î.-P.-É. à titred’aide de camp du lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick.

Avis

Avis d’une décision de dissoudre les corporations provincialeset d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovin-ciales

Avis d’une décision de dissoudre les corporations provincialesSachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporationscommerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations suivan-tes en vertu de l’alinéa 139(1)c) de la Loi, puisque lesdites corporationsont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou docu-ments requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la pu-blication du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourradissoudre lesdites corporations.

Loi sur les corporationscommerciales

Notice of a decision to dissolve provincial corporations and tocancel the registration of extra-provincial corporations

Notice of decision to dissolve provincial corporationsTake notice that the Director under the Business Corporations Act hasmade a decision to dissolve the following corporations pursuant toparagraph 139(1)(c) of the Act, as the said corporations have been indefault in sending to the Director fees, notices, and/or documents re-quired by the Act. Please note that 60 days after the date of publicationof this Notice in The Royal Gazette, the Director may dissolve thecorporations.

Business Corporations Act

050923 050923 N.B. Ltd.052961 052961 N.B. Inc.055621 055621 N.B. LTD.055636 055636 N.B. LTD.647645 125 MacNaughton Avenue Ltd.507891 507891 N.B. INC.510532 510532 N.B. Ltd.510576 510576 N. B. LTD.512861 512861 New Brunswick Ltd512954 512954 N.B. Ltd.513187 513187 N.B. LTD.609493 514039 NB Inc.515534 515534 N.B. Inc.515571 515571 NB LTD.609257 609257 N.B. Ltd.609261 609261 N.B. Inc.609322 609322 N.B. LTÉE609351 609351 NB Inc.609356 609356 N.B. Ltd.609584 609584 NB Ltd.615461 615461 N.B. Ltd.615556 615556 N.B. Inc.615660 615660 NB Ltd.615802 615802 N.B. LTD.615819 615819 N.B. Inc.622083 622083 N.-B. Ltée622097 622097 NB LTD.622261 622261 N.B. Inc.622266 622266 N.B. Inc.622483 622483 N.B. Inc.628416 628416 N.B. Ltd.628423 628423 N.-B. INC.628608 628608 New Brunswick Inc.628643 628643 N.B. INC.628704 628704 N.B. Ltd.628709 628709 N.B. Ltd.628885 628885 NB Inc.634905 634905 N.B. Ltd.634983 634983 NB Inc.635129 635129 N.B. Ltd.

635181 635181 N.B. Inc.635188 635188 N.B. Inc.641217 641217 N.B. LTD.641229 641229 NB LTD.641277 641277 N.B. INC.641304 641304 N.B. INC.641458 641458 N.B. Inc.641565 641565 N.B. LTD.645184 645184 N.B. Ltd.647501 647501 N.B. Limited647502 647502 N.B. Limited647533 647533 N.B. Ltd.647551 647551 N.B. LTD.647566 647566 NB Inc.647588 647588 N.B. Ltd.647591 647591 NB Ltd.647688 647688 N.B. Ltd.647715 647715 N.B. Ltd.647840 647840 NB INC.647867 647867 N.B. LTD.647869 647869 New Brunswick Corp.647909 647909 N.B. Ltd.634804 A. HOWE ENTERPRISES LTD.513207 A.W. Myer’s Associates Ltd.628823 ABCIENT TRADE LTD.615612 ABF Dumont Enterprises Ltd622013 ACM Logging Ltd.635169 Acrylicon Canada Distribution Ltd.641308 Action Construction Ltd.647717 Active Motion Brace Shop Inc.641314 AHD Global Equipments Ltd.647744 Alamo Telecom Corp.647725 Allisonian Art Garden Limited609521 AMA Canada Inc.615481 ANDERSEN APARTMENT RENTALS

LTD647476 ANDRE M. LTEE513053 ARPENTAGES FRENETTE SURVEYS

INC.609243 Ashley Moody Trucking Ltd.

647656 Asia Dragon Buffet Ltd.641282 Asia-Housing Canada Inc.647935 ASIAN KITCHEN RESTAURANT INC.000908 ASSURANCE VIENNEAU LTEE -

VIENNEAU INSURANCE LTD.508095 ASSURANCES A. M. LeBLANC INC.647596 AT YOUR SERVICE CONTRACT

DELIVERY LTD.634936 ATC Auto Imports Ltd.647972 Atlantic Custom Kitchens 2009 Ltd.647969 Atlantic Millennium Star Inc.052931 AUBERGE DU PONT ROUGE

LIMITEE628829 Avery Holdings Ltd.634967 B.E.D. PROPERTIES INC.622178 B.S.A. BOAT REPAIR LTD.615789 Baisley’s Interior & Exterior Construction

Ltd.622385 BELLEDUNE GAS & CONVENIENCE

INC.628801 Bradford Stone Masonry Limited036295 BRIDGES FARMS LTD.505893 BRIDGEWAY DEVELOPMENTS

CORPORATION641571 C.U. AdminCo Inc.002779 CALEDONIA CONSULTANTS LTD.002791 CALPEK LIMITED634795 CanaSpec Trading Company Inc.508036 CANNEBERGES SAINT-CHARLES

CRANBERRIES INC.609325 CAPTAIN’S LOOKOUT COTTAGES

LTD.647711 CARICOM FINANCIAL INC.013337 CHARLES PRICE, LIMITED050855 CHECKERS HAIRPORT LTD.501116 CHIPMAN SAWMILL INC./SCIERIE

CHIPMAN INC.615437 CHOPPER RODS INC.628602 CIBS International Inc.043057 COLPITTS’ TREASURE ISLAND INC.

Page 3: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1325 Gazette royale — 19 octobre 2011

505841 COMPTABILITE J.G. LOSIER LTEE045986 COMPUTERIZED ACCOUNTING

SERVICES LTD.641515 Comservice AG Ltd.634775 Concero Properties Inc.647774 Concrete Unlimited Inc.647938 CONFUCIUS CULTURAL EXCHANGE

LTD.505860 COOMBS BROS. LTD.603981 COPYRIGHT OFFICE MACHINES

AND SUPPLIES INC.647765 Coughlan Tree Service Inc.647539 Cruiser Holdings Inc.503383 D & K TOMPKINS & SONS LTD.647896 D.A.S. Developments Inc.043276 D.S.G.C. HOLDINGS INC.641258 DAB HOMES INC.503452 DAIBES HOLDINGS LTD.505869 DIOTTE SAVOIE AUTO LTD.628761 DLT Solutions Canada Inc.647507 DOIRON ENSEIGNES XPRESS SIGNS

INC.005206 DOUG’S AUTO BODY LTD.634884 DR JOCELYN PELLETIER C.P. INC.055651 DR. CONRAD DOIRON

CORPORATION PROFESSIONNELLE

647795 DR. DANIEL CORMIER PROFESSIONAL CORPORATION

052966 DR. MARK A. INMAN OPTOMETRIST PROFESSIONAL CORPORATION

647836 Dr. Suganthan Kayilasanathan Professional Corporation

641203 Dre Renée Chiasson-Basque C.P. Inc.647945 DS-MEDICAL PROFESSIONAL

CORPORATION INC.005278 DUCEY LUMBER LTD.058890 E J HARRIS INC.641081 E.C. Detail Inc.010679 EDGAR MARTIN LTD.647675 Entreprise RRCR Ltée045993 ÉRABLIÈRE SUCRE D’OR LTÉE.647632 EXTERMINATION SANITATION

NORD-EST INC.609329 Extreme Pawns Inc.006165 FERME DE CHAROLAIS GAUVIN

LTEE634866 First Nations Management Services Inc.505941 FOLKESTONE ENTERPRISES LTD.615473 FPC Holdings Inc.634846 Fredericton Foods Inc.647562 FREDERICTON NEWS CHANNEL

INC.040538 G T A CONSULTANTS EN PECHES

FISHERIES CONSULTANTS INC.634926 Galerie Coutellier Gallery Inc.510591 Gamma Investments Ltd.615501 GATEWAY HOSPITALITY PROJECT

MANGEMENT INC.048667 GERRISH DOCUMENT SERVICE INC.615784 GLOOSECAP MUSIC LTD.647567 GOLF RUSH INC.058848 GORMAN USED RESTAURANT

EQUIPMENT INC.007417 GRAND THEATRE LTD.609613 Grandview Residences Inc.634797 GRANITE RESOURCES LTD.634836 Gretzky Construction and Consulting

Services Ltd.603801 Groupe CIESA et Média-CI inc.647790 H & G Development Inc.020866 HAIR-TISTIC LTD.505930 HAUG NORTH AMERICA INC.641261 HD GLOBAL EQUIPMENTS LTD609621 Heabury Holdings Ltd.622405 Highfield Holdings Limited628476 Hit The Road Auto & Rv Ltd.622019 Hometown Communications Ltd.515680 Hughes Development Inc.

635054 Hurricane Shooters Canada Inc.647966 Hypothèque Philo J. Mortgage Inc.053020 IMMEUBLES NADEAU INC. -

NADEAU REAL ESTATE INC.508084 INFORMATION TECHNOLOGY

TODAY INC.501254 INTERNATIONAL IMMIGRATION

SERVICES INC./SERVICES INTERNATIONAUX EN IMMIGRATION INC.

045442 INVESTMENT REALTY SERVICES LTD.

503395 IRVING FLEET SERVICES LIMITED604181 IT BUSINESS ASSOCIATES INC.647535 J. A. Excavation Inc.647950 JASON COREY BUILDING

SOLUTIONS LTD.634852 JAY’S SPORTS BAR INC.510614 JEMSEG SERVICE CENTRE INC.647681 JMS FOODEEZ INC.036238 JOHNSON MANAGEMENT LTD.646742 Jonah Family Renovations Inc.030983 JOS. DUBE & FILS LTEE604134 KAP ENTERPRISES INC.046017 KDB HOLDINGS INC.641374 KLB Wholesale Ltd.628684 KMB Innovation Inc.501287 L & M LASER SALES & SERVICE LTD.052983 L. & R. DIONNE REAL ESTATE LTD.043043 L.E.S. LAVOIE INC.510543 LADIES & GENTLEMEN’S CHOICE

LTD.040532 LAIKOR ENTERPRISES LTD.505933 LAZY RIVER DEVELOPMENTS LTD.509736 LES ENTERPRISES ANDEZ LTÉE053045 LES SERRES LEBLANC LTEE/

LEBLANC GREENHOUSE LTD.635076 Little Rays of Sunshine Inc.609217 LOCK-LEE FARM LTD.002266 M. D.“ MIKE” BREAU AGENCY LTD.628658 M.A.G. Industrial Services Ltd.034588 M.P. REALTY LIMITED053038 M.R. APPRAISAL SERVICES LTD./

LTEE058835 M5 ADVERTISING N. B. LIMITED628523 Magoo Inspections Inc615604 Main Street Multi Repair Inc.647812 MandA Gardens Inc.647821 MARIO RICHARD ROOFING LTD.508078 MARITIME INTERNATIONAL

DISTRIBUTION INC.501170 MAS VENTURES INC.515679 MECIMPEX INC.635213 Menuiserie ParBel Woodworking Inc.615476 Miami Tan (Moncton) Inc.058882 MILLSTREAM HOLDINGS INC.513146 Miracle Heat Ltd.006018 MONARCH REALTY LTD.628620 MRX SIGNS INC.634807 MULLIN GEOMATICS CORP.634784 MULLIN-HOWE GROUP INC.634785 MULLIN-HOWE REALTY INC.052969 MULTI-PUBLICITY N.B. LTD/LTEE647906 MXY ENTERTAINMENT LTD.634796 N.T.F.P. ENTERPRISES LTD.011903 NAMAC SERVICES LIMITED647853 NCC LEASING INC.515568 NeoResins Inc.034559 NEW DAWN VENTURES INC.647676 nGauge Inc.641377 Nico’s Bakery Café Inc.050641 NORM’S PIZZA INC.515538 Nutritec Inc.038351 O’LEARY HOLDINGS LTD.609469 O.A.B. Enterprises Inc.641601 Old Fangled Steeple Ltd.622418 OPEN OCEAN SYSTEMS INC.634872 P R PORT CITY PROPERTIES LTD

048588 P.B. INDUSTRIAL REFRIGERATION LTD.

641212 PERFECTION DRYWALL INC.647522 Perrin’s General Contracting Inc.647823 PETIT DEPANNEUR (2009) LTEE043205 PHARMACIE R. BOUDREAU LTEE647826 Pomar Enterprises Inc.647885 PORT CITY BUILDERS LTD.604139 PropertyGuys.com Bathurst Inc.622185 QAQC CONSULTING SERVICES INC.501198 QUADREN HOLDINGS LTD.641591 QUALITY ROOFING LTD.641263 QUINCAILLERIE GUIGNARD (2009)

LTEE501202 R. A. BARNETT ENTERPRISES LTD.058792 R.H. MCALLISTER LTD.515650 Rabaey Management Consultants Inc.641584 Résidences Mortier Inc.013920 RESTIGOUCHE COAL COMPANY,

LIMITED647758 Revive Auto Shop Ltd.046128 RIVER BEND SALMON HATCHERY

LTD.058829 RIVERGATE HOLDINGS LTD.634825 RIVERSIDE TIRE LTD.513173 Rocket Boat Manufacturing Ltd.628405 Ronnie Murphy Trucking & Excavation

Ltd020843 ROSE FLOWER FARMS LTD.641384 Roussel Electronique Ltée031033 S. N. B. HOLDINGS LTD.609687 S.E. NEWMAN & SON INC.058733 SAM’S GRAPHICS AND

ADVERTISING INC.628716 Saxby’s Pub & Eatery Co. Ltd.615765 Searco Construction Inc.622329 Second Forest Council Inc.501236 SHADRACK FISHERIES LTD.622235 Sharpe Canoes (2005) Inc.641303 SIBSI - Scope International Business

Solutions Inc.503389 SKYRIDGE SYSTEMS INC.647605 Sleep Zone Canada Inc.615506 Sophie J.D. Holdings Ltd.015428 SPARKLE DRY CLEANING LTD.622227 St. Thomas Fish Market (2005) Inc.011457 STERLING W. MULLIN LTD.515518 STOTHART AUTOMOTIVE INC.046194 SUGARLOAF MOUNTAIN

MANAGEMENT LTD.628489 SUMAC GROVE HOLDINGS LTD.641529 Summit Centre Ltd.609381 Sunrise Investments Ltd.647637 Superprevis Canada Inc.615521 T & D Legacy Transport Ltd.647921 T & R SOD FARMS LIMITED647563 Tan Mei Feng Shui Master International

Co. Ltd501284 THIRSTY MULE SALOON LTD.634789 TIMBERLAND REALTY INC.634791 TIMBERVEST FOREST

MANAGEMENT INC.016221 TOBIQUE ESTATES LTD.031047 TOP LINE UTILITY LTD.501169 Tozer Chrysler Jeep Ltd.647773 Trinity Alliance Corporation016469 TURNER DEVELOPMENTS LTD.043111 TWIN BROOKS HOLDINGS LTD.615543 Union Station Ltd.045477 UNITED BAPTIST CEMETERY

(PENNFIELD) LTD.647714 VALPAK OF EASTERN N.B. INC.647861 Vapour 2 Inc.020834 VENEER PRODUCTS OF N. B. (1981)

LTD.628530 Vestas - Alberta V90 Test Turbine Inc.515582 Village Hardware & Building Supplies

Ltd.647828 VIP APARTMENTS INC.

Page 4: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1326 Gazette royale — 19 octobre 2011

036224 WANDLYN INNS LTD./LES AUBERGES WANDLYN LTEE.

615813 William Andrews Company Limited058935 WORLD M.A.T. INC.

647806 WORLDWIDE CLINICAL TRIALS CANADA LIMITED

647494 Wu International Trading Inc.513191 XIOtech (Canada) Ltd.

038389 Y & J LUMBER LTD.609483 Youngdale Farms Ltd.

622051 0734641 B.C. Ltd.641348 1322245 Ontario Inc.647528 7253974 CANADA LIMITED647517 9206-8782 QUÉBEC INC.647618 ALIMENTS CODICIOSO INC./

CODICIOSO FOOD INC.647554 ATLANTIC GREEN ENERGY LTD.632882 Atlas Structural Systems Inc.647377 Canada (East) Films Inc.

647663 CRELOGIX PORTFOLIO SERVICES CORPORATION

615614 FITCHCO ENTERPRISES INC.641423 Flynn Equipment Rentals Ltd.622369 FORT EDWARD EXPRESS CO. INC.071099 GRIFFITH LABORATORIES LIMITED/

LABORATOIRES GRIFFITH LIMITEE

647587 LE GROUPE HARNOIS INC

647273 Les Propriétés Pink Tree Inc. / Pink Tree Properties Inc.

071716 PML MICROBIOLOGICALS, INC.647719 Prima Innovations Inc.647816 Skylink Express Inc.628662 VerifyRx INC.

002436 BRUNSWICK CURLING CLUB INC.634957 Canada East Air Cargo Gateway Inc.020697 CARNAVAL D’AMITIE D’HIVER DE

DIEPPE INC.-WINTER FRIENDSHIP CARNAVAL INC.

006461 CENTRE ÉVOLUTION JEUNESSE / YOUTH EVOLUTION CENTER INC.

091420 CENTREVILLE REGIONAL VAULT INC.

020924 CIMETIERE CATHOLIQUE DE BRANTVILLE LTEE

022014 CLUB D’AGE D’OR LA RENCONTRE DES AMIS DE LAGACEVILLE, INC.

022480 CUMBERLAND BAY COMMUNITY CENTRE INC.

614739 E.W.G. Food Services Ltd.021996 EGLISE CHRETIENNE

EVANGELIQUE BAPTISTE DE TRACADIE INC.

635223 Fondation Vers Ton Rêve Inc.021726 FREDERICTON AMATEUR SPEED

SKATING CLUB INC.025537 FRIENDS OF BEAUBEARS ISLAND

INC.023028 GOLDEN RIDGE INC.628026 Heather Wilbur Memorial Golf

Scholarship Fund Inc.609346 Intercultural Heritage Association Inc.

647685 Iranian Canadian Association of New Brunswick (ICANB) Inc.

641579 La Société de l’éveil critique Inc./The Conscious Awakening Society Inc.

025037 LADIES HOOP CLASSIC, INC.009672 LAWNDALE HOLDINGS INC.023608 LE COMITE D’AUTORITE

PORTUAIRE DE GRANDE-ANSE INC.

003587 LES CHEVALIERS DE ST. QUENTIN INC.

024097 LES RESIDENCES HABITAT SOLEIL RESIDENCES INC.

020913 LES RESIDENCES SENATEUR EDGAR E. FOURNIER INC.

023856 MIRAMICHI RECREATION COUNCIL INC.

011425 MOUNT HOPE CEMETERY COMPANY, LIMITED

023606 MOUNT ZION ASSOCIATE REFORMED PRESBYTERIAN CHURCH INC.

022251 MULTICULTURAL ASSOCIATION OF SAINT JOHN INC.

628764 Musquash Light Station Inc.020854 NEW BRUNSWICK EXECUTIVE

FOREST RESEARCH COMMITTEE INC.

647627 New Brunswick Invasive Species Council Inc.

609291 PASSEKEAG PHEASANT CLUB INC.025794 Sackville Volunteer Firefighters

Association Inc.024851 SAINT JOHN FIREFIGHTERS

HISTORICAL SOCIETY INC.014651 SAINT JOHN ROTARY BOYS CHOIR

INC.023602 TARGETTVILLE RECREATION

CENTER INC.024073 THE NEW BRUNSWICK GOSPEL

MUSIC FESTIVAL INC.015980 THE TANTRAMARSH CLUB, INC.022263 TRUSTEES OF BARNESVILLE

PRESBYTERIAN CHURCH, BARNESVILLE, NEW BRUNSWICK

016534 UNITED COMMERCIAL TRAVELLERS OF AMERICA (BATHURST COUNCIL NO. 827) INC.

024628 VICTORY ASSEMBLY INCORPORATED

023049 WOODSTOCK TRAIL MAKERS - SNOWMOBILE ASSOCIATION INC.

____________________

Notice of decisionto cancel the registration of extra-provincial corporations

Take notice that the Director under the Business Corporations Act hasmade a decision to cancel the registration of the following extra-provincial corporations pursuant to paragraph 201(1)(a) of the Act, asthe said corporations have been in default in sending to the Directorfees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that60 days after the publication of this Notice in The Royal Gazette, theDirector may cancel the registration.

____________________

Avis d’une décisiond’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales

Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporationscommerciales, a pris la décision d’annuler l’enregistrement des corpo-rations extraprovinciales suivantes en vertu de l’alinéa 201(1)a) de laLoi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir auDirecteur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez aviséque 60 jours après la date de la publication du présent avis dans laGazette royale, le Directeur pourra annuler l’enregistrement desditescorporations extraprovinciales.

Avis d’une décision de dissoudre les compagnies provincialesSoyez avisé que le Directeur, en application de la Loi sur les compa-gnies, a pris la décision de dissoudre les compagnies suivantes en vertude l’alinéa 35(1)c) de la Loi, puisque lesdites compagnies ont fait dé-faut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents re-quis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publicationdu présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourra dissoudrelesdites compagnies.

Loi sur les compagnies

Notice of decision to dissolve provincial companiesTake notice that the Director under the Companies Act has made a de-cision to dissolve the following companies pursuant to paragraph35(1)(c) of the Act, as the said companies have been in default in send-ing to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act.Please note that 60 days after the date of publication of this Notice inThe Royal Gazette, the Director may dissolve the companies.

Companies Act

Page 5: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1327 Gazette royale — 19 octobre 2011

SACHEZ QUE, conformément aux articles 12.3 et 12.31 de la Loi surl’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations com-merciales, L.R.N.-B. de 1973, chap. P-5, le registraire a l’intention, envertu de ladite loi, d’annuler l’enregistrement des certificats de sociétésen nom collectif indiquées à l’annexe « A » ci-jointe et des certificatsd’appellations commerciales des commerces indiqués à l’annexe « B »ci-jointe, en raison du fait que ces firmes ou commerces ont négligé defaire enregistrer des certificats de renouvellement conformément àl’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7) de ladite loi, selonle cas.SACHEZ AUSSI qu’en tout temps après la date d’expiration de trente(30) jours à partir de la date de publication du présent avis, le registrairepeut annuler l’enregistrement desdits certificats de sociétés en nomcollectif et certificats d’appellations commerciales.

Loi sur l’enregistrement dessociétés en nom collectif et

des appellations commerciales

TAKE NOTICE that, pursuant to sections 12.3 and 12.31 of the Part-nerships and Business Names Registration Act R.S.N.B., 1973, c. P-5,the Registrar under the said Act intends to cancel the registration of thecertificates of partnership of the firms set forth in Schedule “A” an-nexed hereto and the certificates of business names of the businessesset forth in Schedule “B” annexed hereto by reason of the fact the saidfirms and businesses have failed to register certificates of renewal inaccordance with paragraph 3(1)(b) or (c) or subsection 3.1(2) or 9(7),as the case may be applicable, of the said Act.

FURTHER TAKE NOTICE that at any time after the expiration date ofthirty (30) days from the date of publication of this Notice, the Regis-trar may cancel the registration of the said certificates of partnershipsand certificates of business names.

Partnerships and BusinessNames Registration Act

Schedule “A” / Annexe « A »Certificates of Partnerships / Certificats de sociétés en nom collectif

627727 BATEAU SIVRET - GARCEAU352446 BLOOMFIELD RIVER-VIEW627441 G & C Network Consultants627619 G.S.J. PRODUCTIONS NB627321 Inner Essence347670 Les Investissements AGM350363 LITTLE ART STUDIO

347983 LMS Enterprises350196 M & M TROPHIES & AWARDS627878 MacLEOD’S TOO627725 Mand Construction627707 S + M Group313326 SHADOW LAWN INN627886 SIS Décor Consulting

627792 SNR SIDING622001 STARVIN MARVIN’S PIZZA & CHILI

FACTORY627639 Susurrus for educational change347669 Tom & Judy Dalling’s Farm627728 Wolter Land Estates

627626 A B Drost Transportation Services350168 A P B VENTES/SALES REG.347755 A. W. CAVANAGH FUNERAL HOME

“HILLSLEY CHAPEL”627737 A.M.B. Reno337350 ACCENT HOMES & RENOVATIONS627652 Access Computer Clinic626972 AFFORDABLE STORAGE627553 Allain Multi Transport345325 ALLEN’S COUNTRY CORNER627475 ALLEN’S WELDING & SUPPLY627515 AMMON STANDARDBREDS627845 Artisan Patrick Côté334322 ATLANTEK T.V. REPAIR347861 Atlantic Pumps & Equipment334874 ATLANTIC SALMON MUSEUM315820 ATLANTIC TAX & ACCOUNTING

SERVICE627562 Atlantic Technology Solutions347724 ATLANTIC TURBO 2000352625 AWSOME PW CONSULTING

SERVICES627666 Back it up 1st Computer Repairs350361 BAKERS DOZEN625489 Bargain Tires Auto Sales & Mobile Wash350522 BATTERY HOUSE337554 BEATS & BYTES627534 BEAUTIFUL CALF PRODUCTIONS627623 Beauty of Nails & Esthetics347420 Beaver Springs350325 Belleisle Road Body & Paint626242 Bello Vista Hair Design

348003 Big Wheels Auto Sales627644 Bijou Nails324750 BIRCH HILL DRAPERY627798 Blue Water Technical Services347793 Bob MacFarlane Light Trucking627533 Bobby Crook Drywall, Finishing &

Painting347787 BOCABEC COUNTRY GARDEN

COTTAGES627521 Body & Sole Dancewear347800 Body Enhancement Salon627834 Body Rescue627633 Bonami Enviro Restoration347607 Boutique J’Aime Tout627564 Breezes Salon627744 BREW & CUE BILLIARDS352519 Brookside Dental Clinic347898 Bruce’s R.V. & Auto Sales627661 BUFF & STUFF Custodial Services627711 BUMP Maternity & More627610 C.D. AUSTIN CONSULTANT627519 C.P.H20 Distributors627629 CANAM’S CLASSIC AND ANTIQUE

AUTO RESTORATION627889 Canoose Camps627822 Canutour Travel Services313654 CAPITAL BUSINESS ASSOCIATES342842 CAPTAIN DAN’S614150 CARING FRIENDS ACTIVITY

CENTER627717 Carolyn’s Creations627818 Casse-Croûte La Marmite

627849 Centre Dentaire Boucher Levesque Maltais Dental Centre

621981 CHAMO CONSTRUCTION621984 Chef Scott’s Culinary Academy621978 Chef Scott’s Culinary Vacation627813 Chicken Daddy’s627318 CHRISTINE’S CONFERENCE

SERVICES350374 Clarity Creations627578 Cleanse Body & Soul “444”627875 Coaching Edge627800 Coiffure Lounge347757 Coiffure Nou“vo” Style621971 Complete Family Care627697 COMPTABILITÉ G. MERCURE627503 CONFORT ET RELAXATION

ESTHÉTIQUE350271 CONSTRUCTION J.R.L.627474 Craig Scott Consulting Services627512 Creative Fitness350464 CRUISE East350390 CUT 2000 MEN’S HAIRSTYLING627898 D & R SNOW REMOVAL SERVICES627821 D. A. Lyons Trucking621779 D. Coy Carpentry627532 D. W. ’S ENTERPRISE627780 Daddy’s Pizza Bar Sportif627838 DaMire Sale & Distribution627485 Danford Signs627678 DANMO ENTERPRISES350261 Danny’s Trophy Plaques627453 Debra M Davies Enterprises

____________________________________________________

Schedule “B” / Annexe « B »Certificates of Business names / Certificats d’appellations commerciales

Page 6: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1328 Gazette royale — 19 octobre 2011

347765 DELPHINUS COMPUTER SYSTEMS350459 DEMCO SATELLITE350460 DEMCO VIDEO627776 DENIS BABIN PARTS &

ACCESSORIES348039 Dépanneur Presto347976 DERMALASER ENR.627825 Destroyer Films627510 Diamond Coach (2006)627657 DIDI’S MANICURE PEDICURE627833 Draco Distribution & Sales347969 DRS Distributors627611 Dunfield Contracting350114 Dunn-Rite Ventilation Service350171 DUSANKA’S EURO-HAIR-SHOP337300 ELLIE-GANT GROOMING627846 Elm City Landscaping627706 EMERYHOUSE SPECIAL CARE

HOME352855 ENTERPRISE VITALITY334483 ENTREPRISES LES DEUX AILES627686 ESCAPE Spa, Salon, Studio627692 Evans Environmental Consulting350414 EVOLUTION MODE ENRG.627905 FERN’S GUITAR SHOP AND PIANO

TUNING348038 FIRST NATION FISH BUYER627881 First-In Training & Supplies627759 Fit for Her - Riverview347743 FITWORKS EQUIPMENT350448 FITZFOR350255 FIVE STAR COMMUNICATIONS621983 Foodies & Wineo’s International Gourmet

Grocers350164 FUR-ever Friends Dog Grooming621958 G&G Arty-Crafty Trading350103 Gee B’s Odd Jobs627811 GENESIS FRESH WATER SALES350512 GLOBAL STORAGE SOLUTIONS627837 Golden Grove Convenience Store621952 GOOSE LAKE CONSTRUCTION347821 Gordie’s Auto Body337407 GORDON M. COTTON &

ASSOCIATES345318 Grande-Anse Auto347698 Ha Ha Estate337396 HAMPTON DENTAL CLINIC627443 Happy Wok Rice & Noodle House627826 HASTE Accounting, Bookkeeping and

Business Services347531 HATHAWAYS AUTO REPAIR SHOP347782 Heavenly Hair627676 Hemi-House - Hi Performance Customs621522 HENRY’S GIFTS & CRAFTS627865 Hillcrest Spa627900 HOLIDAY RESTAURANT627420 Hoyts Flowers and Decor340228 HUNGRIES DINER350323 I AM SPECIAL DAYCARE627772 i Home334533 IMAGERI PHOTOGRAPHIE

COMMERCIALE327448 INN ON THE COVE627703 INPLEX FACILITY LOGISTICS627719 Introducing The New You627440 Inventaire immobilier NB Home

Inventory352742 INVESTMENT SOLUTIONS350395 IT SOLUTIONS352667 J N M CONSULTING627746 J.R. Auto Plus Sales347917 JAB Sport Management Consulting627541 Jacquie’s Blue Charm Lodge350502 Janine Vending Machines327339 JAPAN KARATE ASSOCIATION (JKA)

OF NEW BRUNSWICK627520 Jaywalk Media352558 JCB Finance

350192 JEAN ST-ONGE AUTO SALES627588 John Trapé Consulting627775 K&G Enterprises627730 Kara Fecteau Esthetics350408 KEDDY’S MOTOR INN &

RESTAURANT345350 Kingsclear Mushrooms347790 KIT KISH INFORMATION

TECHNOLOGIES627589 L.E. Educational Consultants627768 La Brasserie du Village de Paquetville627556 Lanie’s Place348025 LEADING EDGE GRAPHIX350224 LEO’S UPHOLSTERY347860 Life Style WoodWorking627439 Lighthouse Candles348026 LILLY FAMILY CHIROPRACTIC

CENTRE348033 LINDA VIOLETTE ACCOUNTING350331 Lisa’s Treasure Box627767 Little China347953 LNB BODY SHOP & PAINTING350278 London Lumber 2000627712 Lucy Pink Publishing627912 Lynne’s Photo350413 M. P. Contractor627864 M.Davis Signature Interiors350349 M.T. BOTTLES350204 MACARTHUR’S FLOWER SHOP627489 Magie des Costumes enr.627586 Maja Padrov Pottery627583 Manchester Autoworks627451 Marius Search Consulting627595 Marna Architectural Technology602456 MARTY’S ELECTRIC627598 Matthew Baglole Historical Research

Consulting627904 Merrill Lynch Capital627758 Meubles Signature615290 MILL STREAM LANE CONSULTING352515 MIRAMICHI OPTOMETRY CLINIC334693 MIRAMICHI OUTFITTING CO.347903 MITTON’S TOWERS & ANTENNA

MAINTENANCE627624 Moeburg’s Mini Mart352577 MULVIHILL INSTITUTIONAL ASSET

MANAGEMENT352578 MULVIHILL STRUCTURED

PRODUCTS627653 Musique Urbaine / Urban Music342537 NATHALIE POIRIER CAMIONNEUR

& SLASHER334605 NATURAL GOLD627807 Nebulink Computers347445 New Brunswick Play Therapy Association627835 New Choices 4 You350253 NICOLE HERRELL INVESTMENTS627538 NO NAME REALTY347922 Noah’s Ark Country Crafts & Gifts347995 O’DONNELL’S COTTAGES &

EXPEDITIONS350329 Oil Can Harry’s329444 OLD TYME CONTRACTING315998 ORIENTAL HOUSE OF LEE627509 P.M. I. Excavation334864 PADGETT BUSINESS SERVICES OF

SAINT JOHN, N.B.345441 Pano’s II627753 Pansy Patch347720 PARKWOOD SUITES347890 Paysabo315980 PERMA-SHINE627517 PG Carpentry Services627124 Phil’s Trucking627385 PINWHEEL QUILTING SHOP627501 PM Counsel627465 Pool Room Chez Luc350232 Practical Home Services

627498 Pretty Woman627734 Princess Daycare621283 Productions Acadieclick347752 Prototec627761 Quality Mobile Steam Wash627547 Realty Executives Saint John627773 REBKAT FINANCIAL SERVICES627762 RENDEZ-VOUS HYUNDAI627621 RénOlive627867 Republicom stratégies marketing

strategies627625 Residential Well Services627893 Rioux Excavating 2005345349 River Breeze Mushrooms627859 Riverlea Hair Studio627494 Robert Gionet Rénovations627729 Russell MacKinley General Contractors347759 S. Murray Auto Body350328 SALON LA FUREUR621975 Salon Nineteen627756 Sandy’s Fashion Nails627642 Scentsations Bath Products627823 Scissors Edge Studio627544 Second Chance Locating627224 Service Camp Plus347845 SHEARER SPRINKLER LAYOUTS627757 Sherwood Automotive Canada350158 SIGNS BY CAROLE627526 Simply Clean Services627528 Simply Healing621278 SOCIETE D’AIDE DU

DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES DE LA PENINSULE ACADIENNE

350190 Soleil Levant - Communauté Restigouche-Ouest

347951 SPENCER ENVIRONMENTAL627705 Stainless Manchu Music350419 Ste. Anne’s Court Retirement Residence307481 STONE’S ELECTRONICS311844 STRIKES AND SPARES627555 Strugglers347608 STUDIO BELLEVUE COIFFURE

UNISEX627915 SUCOMA GRILL347682 SUNCOR PLUMBING & HEATING

REG’D.627125 Sy-bel (le) esthétique/spa627774 Tenue de livre MC Bookkeeping324485 TÊTE À TÊTE627525 The Colonel’s In Bed and Breakfast342710 THE COURT HEALTH AND FITNESS

CLUB621844 THE FOCUS GROUP ATLANTIC627491 The Greener Choice Property Care621903 THE NEW BRUNSWICK RAILWAY

MUSEUM627793 THE PEARL AT THE FALLS627613 The Seaside Peddler347815 The Whale Store627884 Thousand Answers627668 Three Sisters News350284 Ti-Joe’s Convenience Store337305 TIDY DOGS350358 TIMBER RIVER ECO FARMS621965 Tina’s Tasty Treats dba Candy Bouquet627563 TMRC Consultants627735 TNT Construction & Maintenance350184 TOBIQUE COMFORT350243 Toiles et Auvents 2000627720 Top Gun Divers627468 Trans Maritime Shuttle Service350317 TREASURE HUT GIFTS627817 TREETOPS347999 TRENDY ACCENTS352505 Triple S Trucking627607 Two C’s Enterprises347843 Ultra Nettoyage

Page 7: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1329 Gazette royale — 19 octobre 2011

627831 VALKAM’s Choice337493 VALLEY PETROLEUM350269 VANTAGE ADVERTISING AND

DESIGN352770 VERTIGO COIFFURE & ESTHÉTIQUE

ENRG.627862 Vienneau Wreaths

350293 VMAG Construction & Renovations347856 WALNUT WONDERS347941 Wanda’s Cut & Curl350226 WASHBURN CONSULTING627511 Wholesome Touch Massage Therapy627508 Wiggans Organics350259 WMS Water Management

627897 WONG WING627617 Wood’s Woodworking340260 WRIGHT ANALYTIC627576 X CHIEF627675 Xlerated Business Outsourcing

Sumation Consulting N.B. Inc. Grande-Digue 659591 2011 09 29

Atlantic S.C. Ltd. Saint Andrews 659649 2011 09 21

659666 NB Inc. Moncton 659666 2011 09 21

659670 N.B. LTD. Moncton 659670 2011 09 21

DIALOG New Brunswick Architecture Engineering Interior Design Planning Inc.

Saint John 659673 2011 09 26

659686 NB Inc. Moncton 659686 2011 09 22

Perfect Climate Inc./Climat Parfait Inc. Saint-André 659687 2011 09 22

Leger Harvesting Inc. Rogersville 659690 2011 09 22

659691 NEW BRUNSWICK INC. Fredericton 659691 2011 09 22

Brancher Holdings Inc. Fredericton 659693 2011 09 23

Kelly’s Grading Inc. Blackville 659701 2011 09 23

Max Sport Performance Inc. Moncton 659702 2011 09 23

CHALEUR CAREER ASSESSMENT LTD. Dalhousie 659704 2011 09 23

659706 N.B. Inc. Fredericton 659706 2011 09 23

Rivers Edge Estates Ltd. Fredericton 659712 2011 09 23

659713 NB Inc. Moncton 659713 2011 09 23

659714 N.B. Ltd. Saint John 659714 2011 09 23

659715 N.B. Ltd. Saint John 659715 2011 09 23

Lingley’s Property Maintenance Ltd. Fredericton 659718 2011 09 24

659725 New Brunswick Inc. Woodstock 659725 2011 09 26

COASTAL AUTO REPAIR LTD. Saint John 659726 2011 09 26

My New Bathroom Inc. Saint John 659727 2011 09 26

Le Groupe de Pêcheurs de Cap-Pelé Inc. Shediac 659728 2011 09 26

Fitness Mechanix Ltd. Moncton 659729 2011 09 26

D B R Construction Ltd. Moncton 659730 2011 09 26

Loi sur les corporations commercialesBusiness Corporations Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commercia-les, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Page 8: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1330 Gazette royale — 19 octobre 2011

Infinity Distribution Ltd. Riverview 659731 2011 09 26

659732 N.B. Inc. Moncton 659732 2011 09 26

659733 N.B. Inc. Saint John 659733 2011 09 26

Stilleren Consulting Services Ltd. Bayside 659734 2011 09 26

TGA Oakland First Melville Ltd. Moncton 659736 2011 09 27

TGA 151 Queen Ltd. Moncton 659737 2011 09 27

TGA Redmond Vail McAleese Ltd. Moncton 659738 2011 09 27

TGA Evangeline & Laurier Ltd. Moncton 659739 2011 09 27

TGA 6 Donald Ltd. Moncton 659740 2011 09 27

TGA Ivan Ltd. Moncton 659741 2011 09 27

BEUMER Group Canada Corp. Saint John 659742 2011 09 27

659744 N.-B. INC. Lamèque 659744 2011 09 27

B.M.B.J. RENTALS INC. Moncton 659745 2011 09 27

STL Financing & Investments LTD. Moncton 659746 2011 09 27

659748 N.B. Inc. Moncton 659748 2011 09 27

kgbdeals Canada Inc. Saint John 659753 2011 09 27

INNOVEX DEVELOPMENT INC. Moncton 659755 2011 09 27

TRL PitStop Auto Repair Ltd. Bathurst 659757 2011 09 27

WHM Canada Inc. Saint John 659758 2011 09 27

Messler Salmon Camp Ltd. Fredericton 659759 2011 09 27

Leslie Holmes Logging Ltd. Juniper 659769 2011 09 28

Allura Medical Aesthetics and Surgery Inc. Dieppe 659771 2011 09 28

659773 NB Ltd. Fredericton 659773 2011 09 28

MAAAX Corporation Saint John 659774 2011 09 28

B & W GREEN NET LTD. Rothesay 659777 2011 09 28

659780 NB INC. Saint John 659780 2011 09 28

659781 NB Inc. Moncton 659781 2011 09 28

659782 N.B. Ltd. Moncton 659782 2011 09 28

659783 N.B. Inc. Bouctouche 659783 2011 09 28

Actual Light Media Ltd. Saint John 659784 2011 09 28

Tiffany Holdings Limited Saint John 659789 2011 09 29

Killarney Trails Limited Fredericton 659791 2011 09 29

ReDo Holdings Ltd. Dieppe 659794 2011 09 29

Mike Gallant Consulting Inc. Grand Barachois 659798 2011 09 29

659806 N.B. Inc. Moncton 659806 2011 09 29

Eastern Pro Electric Ltd. Quispamsis 659809 2011 09 29

Ozzy MacKay Financial Services Inc. Moncton 659810 2011 09 29

Page 9: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1331 Gazette royale — 19 octobre 2011

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMBusiness Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

In relation to a certificate of incorporation issued on September 29, 2011 under the name of “ReDo Holdings Ltd.”, being corporation #659794,notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the name of the incorporatorfrom “Gene Collette” to “René Collette”.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 29 septembre 2011 à « ReDo Holdings Ltd. », dont le numéro decorporation est 659794, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé faisant passer le nom fondateur de « GeneCollette » à « René Collette ».

_____________________________________________________

In relation to a certificate of incorporation issued on September 29, 2011 under the name of “Ozzy MacKay Financial Services Inc.”, being corpo-ration #659810, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the nameof the corporation from “Ozzy MacKay Financial Services Inc.” to “Ozzie MacKay Financial Services Inc.” and correcting the name of the in-corporator and director from “Ozzy MacKay” to “Ozzie MacKay”.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 29 septembre 2011 à « Ozzy MacKay Financial Services Inc. », dontle numéro de corporation est 659810, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé faisant passer le nom de lacorporation de « Ozzy MacKay Financial Services Inc. » à « Ozzie MacKay Financial Services Inc. » et corrigeant le nom du fondateur et admi-nistrateur de « Ozzy MacKay » à « Ozzie MacKay ».

_____________________________________________________

In relation to a certificate of incorporation issued on October 4, 2011 under the name of “Whitewater Group Ltd.”, being corporation #659876,notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the name of the directorfrom “Rodney A. Card” to “Rodney N. Card”.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 4 octobre 2011 à « Whitewater Group Ltd. », dont le numéro decorporation est 659876, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé faisant passer le nom de l’administrateurde « Rodney A. Card » à « Rodney N. Card ».

_____________________________________________________

Best Buy Medical Supplies Inc. Moncton Nouvelle-Écosse /Nova Scotia

659578 2011 09 16

Express Fashion Apparel Canada Inc. Saint John Canada 659642 2011 09 19

_____________________________________________________

Ermen Plumbing & Heating Ltd. 005939 2011 09 28

BUSHVILLE ANIMAL CLINIC LTD. 032008 2011 09 23

H.A.T. ELECTRIC INC. 048321 2011 09 28

A & J HANNA CONSTRUCTION LTD. 050579 2011 09 29

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpo-rations Act, a certificate of continuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de prorogation a été émis à :

Previous ReferenceJurisdiction Number Date

Registered Office Compétence Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré antérieure référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 10: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1332 Gazette royale — 19 octobre 2011

TRANS EAST TRAILERS LTD. 502242 2011 09 29

Hanna Group Inc. 647552 2011 09 29

_____________________________________________________

608215 NB Ltd. M&M Demolition Inc. 608215 2011 09 23

620901 N.B. Ltd. Select Kitchens Inc. 620901 2011 09 26

Mexicali Rosa’s St. John’s Inc. 648008 N.B. Inc. 648008 2011 09 28

GMCR Canada Holding Inc./Holding GMCR Canada Inc.

Van Houtte Holding Company Limited 654794 2011 09 25

ENCORE ATM-POS INC./ENCORE GAB-TPV INC.

G S NATIONAL INC. 656091 2011 09 27

Monte Cristo Resources Ltd. Monte Christo Resources Limited 657047 2011 09 29

IMPRIMERIE OPTIMUM PRINTING INC. Imprimerie Dynamique (2011) Inc. /Dynamic Printing (2011) Inc.

657610 2011 09 23

Select Granite & Kitchens Ltd. 659715 N.B. Ltd. 659715 2011 09 28

_____________________________________________________

Louis Motel Limited/Limitée Edmundston 010074 2011 09 27

POINT PARK ESTATES LTD. Moncton 013212 2011 09 23

LYNMAN DEVELOPERS LTD. Moncton 036367 2011 09 21

SWIFTTIDE MARINE LTD. Oromocto 041727 2011 09 21

FIRST RATE DRIVER INSTRUCTION LTD. Fredericton 500703 2011 09 27

SERVICES PHARMACEUTIQUES LANCTIN LTEE Dieppe 501118 2011 09 21

FTSI CANADA, LTD. Saint John 514242 2011 09 26

610877 N.B. Ltd. Bloomfield 610877 2011 09 26

Roach’s Ethanol (New Brunswick) Inc. DSL de Grand-Sault / LSD of Grand Falls

627179 2011 09 21

LABTECHSECURITIES LIMITED Saint John 628935 2011 09 21

Compellent Technologies Canada, Inc. Saint John 637140 2011 09 21

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment which includes a change inname has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification contenant un changement de raisonsociale a été émis à :

DatePrevious name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de dissolution a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Page 11: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1333 Gazette royale — 19 octobre 2011

CENTRE ACERICOLE TDS MAPLE CENTER INC.

Saint-Quentin PrincewaterhouseCoopers Inc. 059318 2011 11 26

_____________________________________________________

CENTER FOR ARTS & TECHNOLOGY ATLANTIC CANADA INC.

Colombie-Britannique /British Columbia

500071 2011 09 14

_____________________________________________________

POLLOCK COVE COTTAGES INC. 042507 2011 09 27

053369 N.-B. LTEE 053369 2011 09 23

056641 N.B. INC. 056641 2011 09 27

607124 N.B. Ltd. 607124 2011 09 26

The Hammersley Corporation 624553 2011 09 22

RHA Industries LTD. 637555 2011 09 26

Vintage Bistro & Lounge Ltd. 640861 2011 09 26

_____________________________________________________

PRODUITS DU BOIS G.L. INC. Québec / Quebec I. Gérald LévesqueEdmundston

659463 2011 09 21

AVIVA WARRANTY SERVICES INC. Ontario Michelle A. GionetSaint John

659604 2011 09 19

Assurance Restoration Inc. Ontario Jamie StoreyShediac

659605 2011 09 23

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, notice of the appointment of a receiver or a receiver-manager of the following corporations has been received:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un avis de nomination d’un séquestre ou séquestre-gérant pour lessociétés suivantes a été reçu :

Receiver or ReferenceReceiver-Manager Number Date

Registered Office Séquestre ou Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré séquestre-gérant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of discontinuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de cessation a été émis à :

DateJurisdiction of Continuance Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Compétence de prorogation Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of revival has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de reconstitution a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporationhas been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a étéémis à :

ReferenceNumber Date

Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

Page 12: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1334 Gazette royale — 19 octobre 2011

Victaulic Company of Canada ULC Nouvelle-Écosse / Nova Scotia

SMSS Corporate Services(NB) Inc.Saint John

659617 2011 09 20

National Salvage & Service Corporation Indiana Deborah M. PowerFredericton

659633 2011 09 20

SQUARETRADE, INC. Delaware SMSS Corporate Services(NB) Inc.Saint John

659698 2011 09 23

CANDU ENERGY INC. Canada SMSS Corporate Services(NB) Inc.Saint John

659743 2011 09 27

Alpha Technologies Ltd. Colombie-Britannique / British Columbia

Mathieu BoutetMoncton

659756 2011 09 27

Liz Claiborne Canada Inc. Canada SMSS Corporate Services(NB) Inc.Saint John

659788 2011 09 28

_____________________________________________________

CIBC Asset-Based Lending Inc. CIT Business Credit Canada Inc.Crédit aux entreprises CIT Canada inc

077791 2011 09 20

Amalgamated Financial Group (Canada) Ltd. Can-Collect Solutions Inc. 652387 2011 09 20

_____________________________________________________

Groupe Restaurants Imvescor Inc.Imvescor Restaurants Group Inc.

Groupe Restaurants Imvescor Inc./Imvescor Restaurant Group Inc.

Leonard T. HoytFredericton

658367 2011 09 26

BASF Canada Inc. BASF Canada Inc. SMSS Corporate Services(NB) Inc.Saint John

659618 2011 09 20

Northwood & Associates Inc./Northwood & Associés Inc.

Northwood & Associates Inc./Northwood & Associés Inc.

SMSS Corporate Services(NB) Inc.Saint John

659644 2011 09 21

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment of registration of extra-provincial corporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification de l’enregistrement de corporationextraprovinciale a été émis à :

ReferenceNumber Date

Previous name Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporationhas been issued to the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovincialeissue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-vantes :

ReferenceAgent and Address Number Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour

Page 13: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1335 Gazette royale — 19 octobre 2011

Mostly The Moment Theatre Company Inc. Fredericton 659648 2011 09 21

NEW BRUNSWICK HEALTH PROPERTIES INC. Saint John 659767 2011 09 28

_____________________________________________________

Centre communautaire régional la Nacelle Inc. CENTRE CULTUREL DE CARAQUET INC. 654672 2011 09 26

Shannon May Photography Shannon-May Pringle St. Stephen 659092 2011 09 21

Capital City Builders Steve Williams Fredericton 659453 2011 09 07

LLGG Consultants Lisa Legros Cocagne 659462 2011 09 27

ADORABLE CHOCOLAT Frederic Desclos Shediac 659500 2011 09 12

KENNEBECASIS CONSTRUCTION MEUNERIE NORD-EST (1990)LIMITEE

Penobsquis 659628 2011 09 20

METAFORE FINANCIAL SERVICES Metafore Technologies Inc. Technologies Metafore Inc.

Bernard F. MillerMoncton

659634 2011 09 20

ABRAXIS ONCOLOGY Celgene Inc. Saint John 659643 2011 09 21

EcoFreak Natural Products Natasha Marie Elliott Rusagonis 659653 2011 09 21

Keystone Communities KC PROPERTIES (GP) LIMITED Steven D. ChristieFredericton

659654 2011 09 21

Willow Creek Village KC PROPERTIES (GP) LIMITED Steven D. ChristieFredericton

659655 2011 09 27

Model Nails Thanh Nguyen Dieppe 659656 2011 09 21

Loi sur les compagniesCompanies ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,

letters patent have been granted to:SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres

patentes ont été émises à :

ReferenceNumber Date

Head Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Siège social référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,supplementary letters patent, which include a change in name,have been granted to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettrespatentes supplémentaires, contenant une nouvelle raison sociale,ont été émises à :

DateNew Name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Nouvelle raison sociale Numéro de référence année mois jour

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des

appellations commercialesPartnerships and Business Names

Registration ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and

Business Names Registration Act, a certificate of business name hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-lation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 14: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1336 Gazette royale — 19 octobre 2011

Silver Meadows KC PROPERTIES (GP) LIMITED Steven D. Christie 659657 2011 09 21Fredericton

Lakeside Estates KC PROPERTIES (GP) LIMITED Steven D. Christie 659658 2011 09 21Fredericton

East Coast Village KC PROPERTIES (GP) LIMITED Steven D. Christie 659659 2011 09 21Fredericton

Brookview Community KC PROPERTIES (GP) LIMITED Steven D. Christie 659660 2011 09 21Fredericton

Rosewood Community KC PROPERTIES (GP) LIMITED Steven D. Christie 659661 2011 09 21Fredericton

Allie Cat Computers Frederick Craig Chase Fredericton 659678 2011 09 22

Dynamic Insulation Services Robert Barron Fredericton 659679 2011 09 22

Marc Sonier Construction Marc Sonier Moncton 659681 2011 09 22

Butterfly Effect Studio Zelda Bird Upper Kingsclear 659683 2011 09 22

Cheer Dynasty All-Stars Emily Cuillerier Moncton 659688 2011 09 22

Seagate Technology Seagate Technology Canada Inc. Saint John 659695 2011 09 23

Seagate Recovery Services Seagate Technology Canada Inc. Saint John 659696 2011 09 23

HIGH TECH HEALTH HTH Canada Ltd. Saint John 659699 2011 09 23

IvoryTech Consulting David White Rothesay 659703 2011 09 23

Being Now Initiatives Thomas (Tom) McAvity Queenstown 659705 2011 09 23

En Style Wedding & Events Cindy Cyr WatervilleComté de Sunbury County

659710 2011 09 23

Solutech PC Plus John Hachey Saint-Basile 659719 2011 09 25

Nicholson Dimes and More Enterprises

Chris Nicholson Summerfield 659720 2011 09 25

Miss Kimi Creations Kim Thériault Oromocto 659721 2011 09 25

Express Scripts Canada Pharmacy Express Scripts Pharmacy Atlantic Ltd.

Saint John 659722 2011 09 26

Kinepella’s Natural & Organic Healthcare Products

Jennifer Wallace Keswick Ridge 659724 2011 09 26

Sheldon Welding & Erecting Sheldon Panisiak Moncton 659747 2011 09 27

M&M HOME SOLUTIONS Michel Mazerolle Cormier Village 659749 2011 09 27

EMPIRE LUXURY LIMOUSINES ROCO ENTERPRISES LTD. Miramichi 659750 2011 09 27

RUSTED WRENCH CUSTOMS HILLSIDE ELECTRIC LTD. Moncton 659751 2011 09 27

THE WILD LUPINE HEALTH STORE

Lillian Newton Orange Hill 659754 2011 09 27

RMAC AUTO SALES Richard McMackin The Glades 659762 2011 09 27

MCMACKIN LAND HOLDINGS Shelley McMackin The Glades 659763 2011 09 27

Bartibog River Soaps Julia Trevors Bartibog 659770 2011 09 28

FINCH’S FINE FINISHINGS Jeff Finch Saint John 659772 2011 09 28

L. Hallett Plumbing Lance Hallett Rockland 659786 2011 09 28

Karen’s Coffee Shop Karen Wood Fredericton 659792 2011 09 29

Page 15: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1337 Gazette royale — 19 octobre 2011

WENDY’S HOME STAGING AND INTERIOR DESIGN

Wendy Soontiens Carpenter Saint John 659796 2011 09 29

MARCHE CURRY’S MARKET Sandra Curry Neguac 659797 2011 09 29

BAILA FITNESS STUDIO Rachelle Perkins Saint John 659801 2011 09 29

TOP IMAGE AESTHETICS Ashley Trites Blacks Harbour 659807 2011 09 29

_____________________________________________________

DAVE MACKENZIE & ASSOCIATES

Dave MacKenzie Quispamsis 347501 2011 09 26

Le Point De Beauté Louise Pollock Tide Head 347650 2011 09 26

PROTECT DRIVEWAY SEALING & LINE PAINTING

507535 N.B. Ltd. Miramichi 351600 2011 09 24

A La Douce Brise Esthetique Jessie Despres Cocagne 352092 2011 09 27

Jeweller Alain Desrosiers Joaillier Alain Desrosiers Shediac 352106 2011 09 27

RoyNat Capital RoyNat Capital Inc./ Capital RoyNat Inc.

Raymond F. GlennieSaint John

352788 2011 09 23

RoyNat Capital ROYNAT INC. Raymond F. GlennieSaint John

352789 2011 09 23

BASF CANADA BASF Canada Inc. SMSS Corporate Services (NB) Inc.Saint John

605096 2011 09 20

KETCHUM CANADA Ketchum Canada (2002) Inc. Len HoytFredericton

607765 2011 09 27

MASTER BUILDERS BASF Canada Inc. Saint John 611679 2011 09 20

WATSON BOWMAN ACME BASF Canada Inc. Saint John 611683 2011 09 20

RECYCLE O MAX Eric Dubé Edmundston 626105 2011 09 23

JGF CONSULTING John Fudge Fredericton 626616 2011 09 27

Cliff’s Quality Carpet C. J. & P. ENTERPRISES LTD. Hardwood Ridge 626923 2011 09 27

(Maliseet Fuels II) Lounge I WOODSTOCK FIRST NATION ECONOMIC DEVELOPMENT

Première nation de Woodstock First Nation

627141 2011 09 27

Pink Sushi P&L Atlantic Capital Inc. Saint John 627145 2011 09 27

Squeaky’s Auto Kevin B. Barker Glen Falls 627188 2011 09 27

Northwood/MJM Northwood & Associates Inc./ Northwood & Associés Inc.

Saint John 627282 2011 09 21

BAS Innovations Sebastien Themens Grand-Sault / Grand Falls 627363 2011 09 21

BASF BUILDING SYSTEMS BASF Canada Inc. Saint John 631464 2011 09 20

BASF WALL SYSTEMS BASF Canada Inc. Saint John 631465 2011 09 20

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of businessname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 16: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1338 Gazette royale — 19 octobre 2011

BASF ADMIXTURES BASF Canada Inc. Saint John 631466 2011 09 20

ENERPLAN CONSULTANTS EXP SERVICES INC./LES SERVICES EXP INC.

Fredericton 635753 2011 09 22

bodyshopmall.com BASF Canada Inc. Saint John 643249 2011 09 20

_____________________________________________________

Kelly’s Grading Gray Rapids 607185 2011 09 23

East Coast Village Fredericton 624034 2011 09 21

Rosewood Park Fredericton 627732 2011 09 21

Willow Creek Village Fredericton 628461 2011 09 21

Brookview Mini Home Park Fredericton 629108 2011 09 21

Silver Meadows Fredericton 631689 2011 09 21

Lakeside Estates Fredericton 637799 2011 09 21

Dynamic Deliveries Moncton 651459 2011 09 23

CENTRE CULTUREL DE CARAQUET Caraquet 654670 2011 09 26

HIGH TECH HEALTH Saint John 655594 2011 09 23

TRL PitStop Auto Repair Bathurst 659553 2011 09 27

_____________________________________________________

ARAMARK CTS SMSS Corporate Services (NB) Inc.Saint John

606377 2011 09 26

ARAMARK Clinical Technology Services SMSS Corporate Services (NB) Inc.Saint John

606378 2011 09 26

CARGILL DEICING TECHNOLOGY SMSS Corporate Services (NB) Inc.Saint John

607141 2011 09 20

TECHNOLOGIE DE DÉGIVRAGE CARGILL SMSS Corporate Services (NB) Inc.Saint John

607142 2011 09 20

MDI Storage Services/Services d’entreposage MDI SMSS Corporate Services (NB) Inc.Fredericton

625610 2011 09 02

MDI Brokerage Services/Services de courtage MDI SMSS Corporate Services (NB) Inc.Fredericton

625611 2011 09 02

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-ness or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-merciale a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of change of agent forservice has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-gement d’un représentant pour fin de signification a été déposé :

ReferenceNumber Date

Agent and Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Représentant et adresse référence année mois jour

Page 17: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1339 Gazette royale — 19 octobre 2011

MDI Organic Services/Services de produits organiques MDI SMSS Corporate Services (NB) Inc.Fredericton

625612 2011 09 02

MDI Waste Services/Services de Dechets MDI SMSS Corporate Services (NB) Inc.Fredericton

625614 2011 09 02

MDI Biomedical Services/Services biomedicaux MDI SMSS Corporate Services (NB) Inc.Fredericton

625615 2011 09 02

Mr. Dumpster SMSS Corporate Services (NB) Inc.Fredericton

625616 2011 09 02

MDI SMSS Corporate Services (NB) Inc.Fredericton

625617 2011 09 02

MDI Shredding Services/Services de broyage MDI SMSS Corporate Services (NB) Inc.Fredericton

625618 2011 09 02

MDI Recycling Services/Services de recyclage MDI SMSS Corporate Services (NB) Inc.Fredericton

625619 2011 09 02

MDI Organics/Services de produits organiques MDI SMSS Corporate Services (NB) Inc.Fredericton

625620 2011 09 02

MDI Portable Services/Services de toilettes portatives MDI SMSS Corporate Services (NB) Inc.Fredericton

625992 2011 09 02

_____________________________________________________

Dynamic Deliveries Christopher Robert BettsErnest George Leaman

Moncton 658361 2011 09 23

GONZO LOTTO Justin RobichaudCaroline Roy

Bathurst 659548 2011 09 27

Altered Roots Fusion Mike MailletMike MelansonJoël RobichaudSebastien Michaud

Moncton 659607 2011 09 19

ALPHABET ACADEMY Meghan MacDonaldYvonne Evans

Oromocto 659611 2011 09 19

B & W Long Haul Cargo Services Laurie Kenneth BourgeoisJacqueline Sylvia Woodard

Moncton 659707 2011 09 23

Little Lake Energy Tremblay Consulting ltd.Healy Consulting Ltd.

Quispamsis 659723 2011 09 26

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of partnership hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-ciété en nom collectif a été enregistré :

Address of Business Referenceor Agent Number DateAdresse du commerce Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

Page 18: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1340 Gazette royale — 19 octobre 2011

TRIMESTERS: MASSAGE THERAPY EDUCATION

Cindy McNeelyAllison Hines

Fredericton 626769 2011 09 27

_____________________________________________________

The Lawn Enforcers Dieppe 646979 2011 09 26

MARITIMES & NORTHEAST PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP

Maritimes & Northeast Pipeline Management Ltd.

Saint John 400428 2011 09 20

_____________________________________________________

GOLDMAN, SACHS & CO. Saint John New York SMSS Corporate Services 400604 2011 09 27(NB) Inc.Saint John

Johnson Controls Canada LP Fredericton Ontario Bernard F. Miller 659735 2011 09 26Fredericton

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement de société en nom collectif a été enregistré :

Address ofBusiness or Agent ReferenceAdresse du Number Datecommerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of dissolution of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso-lution de société en nom collectif a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnership Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of limited partnership has been filed by:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite a été déposée par :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Number Date

General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership hasbeen filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite extraprovinciale a été dépo-sée par :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Agent and Address Number DatePrincipal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour

Page 19: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1341 Gazette royale — 19 octobre 2011

Stone 2008-WCP Flow-Through LimitedPartnership

Ontario John D. LaidlawSaint John

636780 2011 09 26

Stone 2008 Flow-Through Limited Partnership Ontario John D. LaidlawSaint John

637790 2011 09 26

Stone 2009 Flow-Through Limited Partnership Ontario John D. LaidlawSaint John

646580 2011 09 26

Stone 2009-WCP Flow-Through Limited Partnership

Ontario John D. LaidlawSaint John

647229 2011 09 26

Qwest Energy 2009-II Flow-Through Limited Partnership

Colombie-Britannique /British Columbia

SMSS Corporate Services(NB) Inc.Saint John

647334 2011 09 26

_____________________________________________________

Tyson Canada Finance LP Nouveau-Brunswick /New Brunswick

Tyson Fresh Meats, Inc. Saint John 608411 2011 09 21

Tyson Canada Finance LP Nouveau-Brunswick /New Brunswick

New Canada Holdings, Inc.

Saint John 608411 2011 09 21

Tyson Canada Finance LP Nouveau-Brunswick /New Brunswick

Tyson InternationalHoldings Sarl

Saint John 608411 2011 09 21

Tyson Canada Finance LP Nouveau-Brunswick /New Brunswick

Tyson Global Holding Sarl

Saint John 608411 2011 09 21

Tyson Canada Finance LP Nouveau-Brunswick /New Brunswick

Tyson AmericasHolding Sarl

Saint John 608411 2011 09 21

Tyson Canada Finance LP Nouveau-Brunswick /New Brunswick

IBP Finance Company of Canada

Saint John 608411 2011 09 21

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limitedpartnership has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale aété déposée par :

ReferenceAgent and Address Number Date

Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of change of limited partnership or extra-provincial limited partnership has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de changement de société en commandite ou de sociétéen commandite extraprovinciale a été déposée :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Number Date

Jurisdiction General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

Page 20: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1342 Gazette royale — 19 octobre 2011

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonceL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Destinataire : Yves Lionel Schmidt, débiteur hypothécaire ori-ginaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertudes dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi surles biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au90, rue Pitt, Saint John (Nouveau-Brunswick), et correspondantau même lot ayant été transféré à Yves Schmidt par l’acte detransfert enregistré au bureau de l’enregistrement foncier le13 juillet 2009 sous le numéro 27418749.Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse, créan-cière hypothécaire. La vente aura lieu le 2 novembre 2011, à11 h, heure locale, au palais de justice de Saint John situé au110, rue Charlotte, Saint John (Nouveau-Brunswick). Voir l’an-nonce publiée dans les éditions des 4, 11, 18 et 25 octobre 2011du Telegraph-Journal.

T. Ryan Seymour, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laBanque de Nouvelle-Écosse, Barker House, bureau 600,570, rue Queen, C.P. 610, succursale A, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5A6; téléphone : 506-458-8572; télécopieur :506-458-9903

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonceL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Destinataires : John Kevin Gilliatt, débiteur hypothécaire origi-naire, Nicole Marie Savoie-Gilliatt, conjointe du débiteur hypo-thécaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée envertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de laLoi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libresitués au 55, rue York, Moncton (Nouveau-Brunswick), et cor-respondant au même lot ayant été transféré à John Kevin Gilliattpar l’acte de transfert enregistré au bureau de l’enregistrementfoncier le 2 février 2006, sous le numéro 21665006.Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia, créan-cière hypothécaire. La vente aura lieu le 2 novembre 2011, à11 h 45, heure locale, à l’hôtel de ville de Moncton situé au655, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick). Voir l’annoncepubliée dans les éditions des 4, 11, 18 et 25 octobre 2011 duTelegraph-Journal.

T. Ryan Seymour, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laBanque de Nouvelle-Écosse, Barker House, bureau 600,570, rue Queen, C.P. 610, succursale A, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5A6; téléphone : 506-458-8572; télécopieur :506-458-9903

________________

Avis de vente

Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Yves Lionel Schmidt, original Mortgagor; and to all otherswhom it may concern. Sale pursuant to terms of the CollateralMortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Actsin amendment thereof. Freehold property being situated at90 Pitt Street, Saint John, New Brunswick, the same lot con-veyed to Yves Schmidt by Transfer registered in the Land TitlesOffice on July 13, 2009, as document number 27418749.

Notice of Sale given by The Bank of Nova Scotia as Mortgagee.Sale to be held at Saint John Court House, Hall located at110 Charlotte Street, Saint John, New Brunswick on the 2nd dayof November, 2011, at the hour of 11:00 a.m., local time. Seeadvertisement of Notice of Sale in the Telegraph-Journal datedOctober 4, October 11, October 18, and October 25, 2011.

McInnes Cooper, Solicitors for The Bank of Nova Scotia, Per:T. Ryan Seymour, Barker House, Suite 600, 570 Queen Street,P.O. Box 610, Station A, Fredericton, New Brunswick,E3B 5A6, Telephone: 506-458-8572, Facsimile: 506-458-9903

________________

Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: John Kevin Gilliatt, original Mortgagor, Nicole MarieSavoie-Gilliatt, spouse of the Mortgagor; and to all otherswhom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgageand the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amend-ment thereof. Freehold property being situated at 55 YorkStreet, Moncton, New Brunswick, the same lot conveyed toJohn Kevin Gilliatt by Transfer registered in the Land Titles Of-fice on February 2, 2006, as document number 21665006.

Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation as Mort-gagee. Sale to be held at Moncton City Hall located at 655 MainStreet, Moncton, New Brunswick on the 2nd day of November,2011, at the hour of 11:45 a.m., local time. See advertisement ofNotice of Sale in the Telegraph-Journal dated October 4, Octo-ber 11, October 18, and October 25, 2011.

McInnes Cooper, Solicitors for The Bank of Nova Scotia, Per:T. Ryan Seymour, Barker House, Suite 600, 570 Queen Street,P.O. Box 610, Station A, Fredericton, New Brunswick,E3B 5A6, Telephone: 506-458-8572, Facsimile: 506-458-9903

________________

Notices of Sale

Page 21: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1343 Gazette royale — 19 octobre 2011

To: David Wayne Tibbetts, of the Town of Rothesay, in theCounty of Kings and Province of New Brunswick, Mortgagor;

And to: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 21 Monaco Drive,in the Town of Rothesay, in the County of Kings and Provinceof New Brunswick.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of thefirst mortgage.Sale on the 18th day of November, 2011, at 10:45 a.m., at theTown Hall in Sussex, 524 Main Street, Sussex, New Brunswick.The Mortgagee reserves the right to postpone or reschedule thetime and date of sale. See advertisement in the Telegraph-Journal.

Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank ofCanada

________________

To: Christopher Arthur Bustard, of the Town of Grand Bay-Westfield, in the County of Kings and Province of NewBrunswick, Mortgagor;And to: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 110 WoolastookDrive, in the Town of Grand Bay-Westfield, in the County ofKings and Province of New Brunswick, PID #00226803.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of thefirst mortgage.Sale on the 18th day of November, 2011, at 11:15 a.m., at theTown Hall in Sussex, 524 Main Street, Sussex, New Brunswick.The Mortgagee reserves the right to postpone or reschedule thetime and date of sale. See advertisement in the Telegraph-Journal.

Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank ofCanada

________________

To: Claudette Mary McKee, of the City of Saint John, in theCounty of Saint John, and Province of New Brunswick and RoyMalcolm McKee, of the City of Saint John, in the County ofSaint John and Province of New Brunswick, Mortgagors;And to: New Brunswick Legal Aid Services Commission,356 Queen Street, Fredericton, New Brunswick, E3B 1B2, LienClaimant;And to: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 86 Glen Road, inthe City of Saint John, in the County of Saint John and Provinceof New Brunswick.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of thefirst mortgage.

Destinataire : David Wayne Tibbetts, de la ville de Rothesay,comté de Kings, province du Nouveau-Brunswick, débiteur hy-pothécaire;Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 21, promenade Monaco, ville deRothesay, comté de Kings, province du Nouveau-Brunswick.

Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulairede la première hypothèque.La vente aura lieu le 18 novembre 2011, à 10 h 45, à l’hôtel deville de Sussex, 524, rue Main, Sussex (Nouveau-Brunswick).La créancière hypothécaire se réserve le droit de reporter la dateet l’heure de la vente. Voir l’annonce publiée dans leTelegraph-Journal.

Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la BanqueRoyale du Canada

________________

Destinataire : Christopher Arthur Bustard, de la ville de GrandBay-Westfield, comté de Kings, province du Nouveau-Brunswick, débiteur hypothécaire;Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 110, promenade Woolastook,ville de Grand Bay-Westfield, comté de Kings, province duNouveau-Brunswick, NID 00226803.Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulairede la première hypothèque.La vente aura lieu le 18 novembre 2011, à 11 h 15, à l’hôtel deville de Sussex, 524, rue Main, Sussex (Nouveau-Brunswick).La créancière hypothécaire se réserve le droit de reporter la dateet l’heure de la vente. Voir l’annonce publiée dans leTelegraph-Journal.

Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la BanqueRoyale du Canada

________________

Destinataires : Claudette Mary McKee, de la ville de Saint John,comté de Saint John, province du Nouveau-Brunswick, et RoyMalcolm McKee, de la ville de Saint John, comté de Saint John,province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires;Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick, 356, rue Queen, Fredericton (Nouveau-Brunswick)E3B 1B2, revendicatrice de privilège;Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 86, chemin Glen, ville de SaintJohn, comté de Saint John, province du Nouveau-Brunswick.

Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulairede la première hypothèque.

Page 22: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1344 Gazette royale — 19 octobre 2011

Sale on the 18th day of November, 2011, at 1:00 p.m., at theCourt House in Saint John, 110 Charlotte Street, Saint John,New Brunswick. The Mortgagee reserves the right to postponeor reschedule the time and date of sale. See advertisement in theTelegraph-Journal.

Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank ofCanada

________________

To: Estate of John Lloyd Barton, of the Town of Sackville, inthe County of Westmorland and Province of New Brunswick,Mortgagor;And to: All heirs and beneficiaries of the Estate of the late JohnLloyd Barton;And to: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 31 RichardsonStreet, in the Town of Sackville, in the County of Westmorlandand Province of New Brunswick.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of thefirst mortgage.Sale on the 23rd day of November, 2011, at 11:00 a.m., in thelobby of the Moncton City Hall, 655 Main Street, Moncton,New Brunswick. The Mortgagee reserves the right to postponeor reschedule the time and date of sale. See advertisement in theTimes & Transcript.

Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank ofCanada

The Royal Gazette is published every Wednesday under theauthority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re-ceived by the Royal Gazette Coordinator, in the Queen’sPrinter Office, no later than noon, at least seven days prior toWednesday’s publication. Each document must be separatefrom the covering letter. Signatures on documents must be im-mediately followed by the printed name. The Queen’s Printermay refuse to publish a document if any part of it is illegible,and may delay publication of any document for administrativereasons.Prepayment is required for the publication of all documents.Standard documents have the following set fees:

NoticesCost perInsertion

Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill

$ 20

Originating process $ 25Order of a court $ 25Notice under the Absconding Debtors Act $ 20Notice under the General Rules under the Law Society Act,

1996, of disbarment or suspension or of application forreinstatement or readmission

$ 20

Notice of examination under the Licensed Practical NursesAct

$ 25

Notice under the Motor Carrier Act $ 30

Notice to Advertisers

La vente aura lieu le 18 novembre 2011, à 13 h, au palais de jus-tice de Saint John, 110, rue Charlotte, Saint John (Nouveau-Brunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit dereporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiéedans le Telegraph-Journal.

Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la BanqueRoyale du Canada

________________

Destinataires : La succession de John Lloyd Barton, de la villede Sackville, comté de Westmorland, province du Nouveau-Brunswick, débitrice hypothécaire;Tous les héritiers et les ayants droit de la succession de feu JohnLloyd Barton;Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 31, rue Richardson, ville deSackville, comté de Westmorland, province du Nouveau-Brunswick.Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulairede la première hypothèque.La vente aura lieu le 23 novembre 2011, à 11 h, dans le foyer del’hôtel de ville de Moncton, 655, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit dereporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiéedans le Times & Transcript.

Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la BanqueRoyale du Canada

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé-ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents àpublier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazetteroyale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, à midi, aumoins sept jours avant le mercredi de publication. Chaqueavis doit être séparé de la lettre d’envoi. Les noms des signa-taires doivent suivre immédiatement la signature. L’Impri-meur de la Reine peut refuser de publier un avis dont une par-tie est illisible et retarder la publication d’un avis pour desraisons administratives.Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.Voici les tarifs pour les avis courants :

AvisCoût par parution

Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loid’intérêt privé

20 $

Acte introductif d’instance 25 $Ordonnance rendue par une cour 25 $Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $Avis de radiation ou de suspension ou de demande de

réintégration ou de réadmission, exigé par les Règlesgénérales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur leBarreau

20 $

Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières etinfirmiers auxiliaires autorisés

25 $

Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $

Avis aux annonceurs

Page 23: October 19 octobre

The Royal Gazette — October 19, 2011 1345 Gazette royale — 19 octobre 2011

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque ormoney order (payable to the Minister of Finance). No refundswill be issued for cancellations.

The official version of The Royal Gazette is available freeon-line each Wednesday. This free on-line service replaces theprinted annual subscription service. The Royal Gazette can beaccessed on-line at:

http://www.gnb.ca/0062/gazette/index-e.asp

Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, atthe Office of the Queen’s Printer, at $4.00 per copy plus 13%tax, plus shipping and handling where applicable.

Office of the Queen’s Printer670 King Street, Room 117

P.O. Box 6000Fredericton, NB E3B 5H1

Tel: 506-453-2520 Fax: 506-457-7899E-mail: [email protected]

Any document under the Political Process Financing Act $ 20

Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9under the Probate Court Act

$ 20

Notice under the Quieting of Titles Act (Form 70B)Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″

$120

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is1/2 page in length or less

$ 20

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice isgreater than 1/2 page in length

$ 75

Any document under the Winding-up and Restructuring Act(Canada)

$ 20

Notice of a correction charge isthe same as

for publishing the original document

Any other document $3.50 for each cm or less

Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte decrédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (établià l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement nesera effectué en cas d’annulation.

La version officielle de la Gazette royale est disponible gra-tuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit enligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve-rez la Gazette royale à l’adresse suivante :

http://www.gnb.ca/0062/gazette/index-f.asp

Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazetteroyale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, pour la sommede 4 $ l’exemplaire, plus la taxe de 13 %, ainsi que les fraisapplicables de port et de manutention.

Bureau de l’Imprimeur de la Reine670, rue King, pièce 117

C.P. 6000Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1Tél. : 506-453-2520 Téléc. : 506-457-7899

Courriel : [email protected]

Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lefinancement de l’activité politique

20 $

Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour dessuccessions

20 $

Avis exigé par la Loi sur la validation des titres de propriété(Formule 70B)

Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 posur 14 po

120 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins enlongueur

20 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page enlongueur

75 $

Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lesliquidations et les restructurations (Canada)

20 $

Avis d’une correction les frais sont les mêmes que ceux imposés

pour la publication du

document original

Tout autre document 3,50 $ pour chaque cm ou

moins

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved / Tous droits réservés